Lobbyist History


Results in Excel format (CSV)

Lobbyist ID: 20215000182 Lobbyist Name: Lawrence, Polly

[Next 20>]
Found 90 matching record(s).  Viewing page 1 of 5.
08/08/2022  20225078175  Add Attachment  Waiver Granted 
08/08/2022  20225078174  Waive fine  Amount waived: $140.00, Waiver granted 
 per Rule 6 
07/07/2022  20225072578  Annual report filed  Fiscal Year: 2021-2022 
07/07/2022  20225072576  Monthly report filed  June 2022 
07/07/2022  20225072574  Delete agent  Name of agent: Matthew La Crue 
07/07/2022  20225072520  Change contact info  Change contact info 
06/27/2022  20225070828  Monthly report filed  May 2022 
06/27/2022  20225070826  Change agent info  Change agent info 
06/17/2022  20225070030  Add Attachment  Filing Correspondence 
06/17/2022  20225070028  Add Attachment  Filing Correspondence 
06/16/2022  20225069517  Monthly report delinquent  Report May/2022. Fines will accrue. 
05/26/2022  20225062871  Fine payment  Amount paid: $80.00 
05/16/2022  20225061120  Monthly report filed  April 2022 
04/21/2022  20225050095  Add Attachment  April 21, 2022 - Notice of Assessed 
 Fines 
04/18/2022  20225048613  Monthly report filed  March 2022 
04/18/2022  20225048612  Add Position  Colorado Municipal Judges Association 
 SB22-099 AME 03/01/2022 -> Present 
04/16/2022  20225047839  Monthly report delinquent  Report March/2022. Fines will accrue. 
03/15/2022  20225033879  Monthly report filed  February 2022 
02/22/2022  20225023556  Add Attachment  Feb. 22, 2022 - Notice of Assessed Fines 
02/16/2022  20225020950  Monthly report filed  January 2022